Stewarts Genealogy
First Name
Last Name
[Advanced Search]
[Surnames]
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Share
Print
Bookmark
Edward Saunderson
1576 - 1617 (41 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Edward Saunderson
[1]
b. 1576 d. 24 Apr 1617
Isabella Shiercliffe
b. 1580 d. 2 Jan 1613
2
Robert Sanderson
[1.1]
b. 1608 d. 7 Oct 1693
+
Sarah Crow
Mary Cross
b. 24 Aug 1606 d. 21 Jun 1691
3
William Sanderson
[1.1.1]
b. 1642 d. 1680
+
Abigail Traine
b. 5 Jun 1677 d. 14 May 1704
Sary Marr
b. 1645 d. 1683
4
Joseph Sanderson
[1.1.1.1]
b. 30 Aug 1680 d. 1736
Sarah Page
5
John Sanderson
[1.1.1.1.1]
b. 13 Dec 1731 d. 28 Apr 1791
Submit Hastings
b. 15 Oct 1729 d. 27 Jun 1822
6
Joseph Sanderson
[1.1.1.1.1.1]
b. 26 Aug 1772 d. 1841
Arathusa Dewitt
b. Jan 1780 d. 10 May 1856
7
Jehiel Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 1804 d. 1896
Amelia A Sheriff
b. 1806
8
Ebenezer Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. Nov 1840 d. 1 Feb 1919
Eliza Jane Howard
b. Oct 1839 d. 12 Feb 1914
9
James Dyer Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 26 Jun 1859 d. 5 Feb 1925
Eva May Stewart
b. Abt 1863 d. 24 Oct 1955
10
Charles A Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. Abt 1888
10
Raymon Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. Abt 1890
10
Bymun J Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. Abt 1891
10
Frederick Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. Jul 1896
10
Ralph Stewart Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 9 Oct 1905
Addie A. Huffstater
b. Jul 1867 d. 22 Feb 1901
10
Frederick E. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 31 Jul 1886 d. 5 Jul 1968
+
Hazel E. Scutt
b. 9 Mar 1895 d. 4 May 1974
10
Charles A Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. Jul 1888
10
Raymond J. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 27 Sep 1890 d. 31 Mar 1946
Myra May Hilton
b. 26 Nov 1890 d. 18 Oct 1975
11
Robert J. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 16 Jul 1914 d. 10 Dec 1988
11
Marion Maude Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 25 May 1917 d. 9 Jun 1917
11
Edna Mae Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3]
b. 6 Mar 1919 d. 20 Nov 2013
Walter Fenton Potter
b. 2 Oct 1912 d. 26 Dec 1988
12
Gary Walter Potter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.1]
b. 4 Nov 1950 d. 3 Jan 2006 [
=>
]
+
Unknown White
Harold F. White
b. 1910 d. 16 Jun 1948
12
Leona White
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.2]
12
Bonnie White
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.3]
12
Raymond White
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.4]
[
=>
]
11
Stanley Edward Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 15 Jan 1922 d. 3 Apr 1992
Shirley Iona Rupracht
12
Heather Ann Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.1]
11
Irene Mary Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.5]
b. 18 Mar 1933 d. 20 May 1989
9
Ellen Louisa Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. Oct 1861 d. 29 Apr 1905
William D. Coon
b. 8 Jun 1856 d. 25 Jun 1921
10
Bertha M. Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 14 Sep 1883 d. 5 Aug 1945
Thomas Fremont Wilder
b. 18 May 1874 d. 9 Apr 1959
11
John Lynn Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 15 Feb 1902 d. 24 Sep 1974
Arvilla Hilda Bush
b. 21 Oct 1898 d. 31 Dec 1979
12
Irene Jane Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 11 Sep 1923 d. 15 Sep 1987
12
John Richard Wilder, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 31 Jul 1925 d. 19 Aug 1993 [
=>
]
12
Nancy Ann Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 7 Apr 1928 d. 31 Jan 2002 [
=>
]
12
William Warren Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.4]
b. 25 Nov 1929 d. 2 Dec 2003 [
=>
]
11
Florence Amelia Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 20 Dec 1903 d. 23 May 1989
Clifford Dexter Montondo
b. 8 Jul 1900 d. 28 Feb 1975
12
Elizabeth Jane Montondo
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 30 Apr 1925 d. 16 Jul 2008 [
=>
]
12
Barbara Jean Montondo
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.2]
b. 17 Dec 1930 d. 25 Apr 2014
11
Baby Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 28 May 1905 d. 30 May 1905
11
Thomas Minot Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 22 Dec 1906 d. 30 Jun 1977
11
Helen Irene Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 2 May 1908 d. 12 Nov 1982
Harold K Grinnell
b. 13 Feb 1907 d. 8 Apr 1986
12
Shirley Ann Grinnell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.1]
12
Jean Marie Grinnell
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.2]
b. 3 May 1931 d. 17 Aug 2001 [
=>
]
11
Charles Draper Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 22 Aug 1910 d. 1 Nov 2002
+
Bessie C. Clark
b. 23 May 1919 d. 3 Nov 2001
11
Beatrice Delia Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7]
b. 21 Sep 1912 d. 4 Dec 1997
John David Thomas
b. 31 May 1906 d. 3 Aug 1982
12
Patricia Elizabeth Thomas
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.1]
b. 15 Oct 1936 d. Nov 2015 [
=>
]
12
John David Thomas
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.2]
b. 27 Jun 1938 d. 4 Dec 2020 [
=>
]
12
Sandra Lee Thomas
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.3]
[
=>
]
12
Sharon Ann Thomas
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.4]
b. 26 Jun 1941 d. 2 May 2009
11
Robert James Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8]
b. 15 Jul 1913 d. 15 Nov 1991
Venita Louise Skinner
b. 4 Oct 1921 d. 13 Feb 2014
12
James Robert Wilder, Jr
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8.1]
[
=>
]
12
Valerie Ann Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8.2]
[
=>
]
12
Joan Louise Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8.3]
b. 12 Nov 1943 d. 9 Jan 2021 [
=>
]
12
Lawrence Thomas Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8.4]
b. 27 Aug 1945 d. 17 Jun 2011 [
=>
]
12
Linda Lee Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8.5]
12
Joseph Stewart Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8.6]
11
Lemuel Edwin Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.9]
b. 20 Jan 1920 d. 11 Jun 1990
Jeanette M Fuller
b. 30 Sep 1922 d. 25 Jan 1978
12
Diane Marie Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.9.1]
b. 22 Apr 1945 d. 30 Mar 2020 [
=>
]
12
Judith Ann Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.9.2]
[
=>
]
12
Wendy Kay Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.9.3]
[
=>
]
11
Marian Elizabeth Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.10]
b. 21 Sep 1921 d. 6 Apr 1937
11
William Howard Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.11]
b. 9 Jan 1924 d. Sep 1924
11
Geraldine Marie Wilder
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.12]
b. 1926 d. 30 Nov 1982
10
Bert Lloyd Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 17 Jun 1885 d. 5 Apr 1961
Flossie Deette Moyer
b. 12 Jun 1891 d. 2 Apr 1961
11
Mildred Genevieve Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 22 Feb 1910 d. 15 Aug 1996
Albert L Gayne
b. 9 Mar 1903 d. 21 Sep 1992
12
Donald Robert Gayne
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1]
+
Frank M. Mandigo
b. 14 Oct 1886 d. 24 Mar 1968
11
Dorothy Ellen Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 4 Oct 1911 d. 9 Aug 1997
Floyd Justus Gayne
b. 1 Feb 1907 d. 11 Mar 1996
12
Beverly Jean Gayne
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.1]
b. 5 May 1929 d. 23 May 2016
12
Mildred Louise Gayne
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.2]
b. 3 Jul 1932 d. 15 Aug 1987 [
=>
]
12
Mary Lou Gayne
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.3]
b. 24 Dec 1934 d. 20 Nov 2014
12
Norma Mae Gayne
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.4]
[
=>
]
12
William Floyd Gayne
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.5]
b. 21 May 1939 d. 16 May 2006 [
=>
]
12
Arthur Francis Gayne
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.6]
b. 30 Mar 1942 d. 8 Jul 2024 [
=>
]
12
Floyd James Gayne
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.7]
11
Burton Leigh Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 6 Mar 1914 d. 30 Jul 1918
11
Robert Lewis Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 20 Jan 1917 d. 23 Dec 1956
Viola Jeanne Gardner
b. 12 Mar 1918 d. 28 May 2009
12
Bonnie Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.1]
12
Debbie Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.2]
12
Bert Anson Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.3]
12
Lee Vernon Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.4]
12
Lauren Marie Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.5]
12
Roberta Viola Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.6]
b. 13 Apr 1948 d. 21 Apr 2007
11
Bert Lloyd Coon, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 29 Nov 1921 d. 19 Mar 2000
Betty Jane Lynn
b. 17 Nov 1922 d. 14 Jan 2016
12
John Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.1]
12
Linda Marie Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.2]
12
David A. Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.3]
b. 19 Sep 1949 d. 3 Nov 2004
10
Florence Edna Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. Jun 1888 d. 31 Jan 1925
Raymond Henry Filkins
b. 18 Jul 1883 d. 29 May 1966
11
Robert Neil Filkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 4 Dec 1906 d. 19 May 1986
+
Beulah Elaine Unknown
b. 1908 d. Aug 1987
11
Dorcas E. Filkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. 23 Apr 1908 d. 4 Aug 1976
Ernest Eugene Seyer
b. 26 Jun 1901 d. 10 Jun 1968
12
Richard Ernest Seyer
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2.1]
b. 20 Apr 1928 d. 9 Jun 1992
12
June Marie Seyer
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2.2]
b. 31 Aug 1931 d. 31 Aug 1931
11
Dorothy E. Filkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 23 Apr 1908 d. 22 Apr 1987
+
Harlan Alva Thornhill
b. 11 Feb 1901 d. 13 Jul 1968
Nelson John Obleman
b. 22 Jul 1909 d. 31 Jul 1972
12
Hollis Ray Obleman
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.1]
b. 17 Aug 1926 d. 6 Aug 1984
12
Robert James Obleman
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.2]
b. 28 May 1930 d. 23 Nov 2011
11
John Henry Filkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 21 Jun 1911 d. 15 Jan 1998
11
Edna Florence Filkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.5]
b. 3 Dec 1912 d. 27 Mar 1953
+
Francis Edward Pappa
b. 15 Aug 1907 d. 23 Oct 1952
11
Clara Filkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6]
b. 1913 d. Bef 1920
11
Raymond Perry Filkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.7]
b. 21 Mar 1919 d. 3 Mar 1986
Arliss Irene Bushaw
b. 13 Dec 1921 d. 3 Mar 1986
12
Carolyn Ann Filkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.7.1]
[
=>
]
12
Thomas John Filkins, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.7.2]
[
=>
]
10
Ivah Belle Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 21 Sep 1893
+
Clarence Dieghton Hewitt
b. 22 Oct 1889 d. Mar 1918
+
Harold Stuart Phillips
b. Abt 1896
10
William Harrison Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. Aug 1897
Winifred Le Ora Nellis
b. Abt 1901
11
Grace E Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1]
11
Harrison M Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.2]
11
Richard L Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.3]
10
Francis Jean Coon
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 28 May 1902
+
William Corrigan
9
David H Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 10 Dec 1861 d. 4 Mar 1948
Minnie M Carey
b. 21 Oct 1865 d. 3 Oct 1933
10
George Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
10
Fred Alfred Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 20 Mar 1888 d. 31 Mar 1964
Lucinda M Deal
b. 29 Jun 1889 d. 28 Jul 1964
11
Helen M. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1]
11
John F. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 7 Aug 1924 d. 13 Dec 2003
+
Clara E. Fitzsimmons
b. 1929 d. 1991
11
Byron F Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. Abt 1927 d. 5 Jul 1930
10
Floyd Earl Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. Dec 1889 d. 8 Mar 1968
Mary Pearl Jamerson
b. 9 Jun 1889 d. 28 Nov 1978
11
Dorothy Belle Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 9 Jun 1910 d. 1988
+
John F. Lewis
b. 10 Jan 1910 d. 20 Aug 1991
10
William Wallace Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 11 Feb 1892 d. 11 Mar 1991
Anna Teressa Laties
b. 12 Apr 1896 d. 5 Nov 1988
11
Dorothy A Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. Abt 1914 d. 2 Sep 1974
10
Mina Mae Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. Jul 1896
+
Unknown Tennyson
+
Loren Howard Burnham
b. Jan 1889
10
Howard Carey Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 6 Feb 1903 d. 14 Nov 1918
+
Margaret Kyre
b. 10 Jun 1873 d. 26 May 1965
9
Harrison Andrew Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 9 Oct 1863 d. 5 May 1945
Laura Belle Shepard
b. 8 Jan 1872 d. 23 Feb 1950
10
Roy E. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 21 May 1889 d. 23 Oct 1953
Florence Jones
b. 18 Aug 1893 d. 6 Sep 1953
11
Stephen Hollister Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.1]
+
Shirley Ann Grinnell
11
Lola Harriet Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 27 Dec 1934 d. 30 Sep 1970
William Frederick Hogarth
12
Terry Lyn Hogarth
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.2.1]
12
Micki Lee Hogarth
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.2.2]
12
Stephen William Hogarth
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.2.3]
11
Alan Paul Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 6 Jun 1936 d. 26 Mar 2006
Diane E. Babcock
12
Cynthia Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3.1]
12
Timothy Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3.2]
12
Sandra Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3.3]
d. 2002
12
Susan Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3.4]
Lola Belle Parsons
b. 23 Aug 1889 d. 12 Dec 1925
11
Helen Louise Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4]
b. 26 Mar 1909 d. 8 May 1970
Frank Lynne Neu
b. 12 Jun 1904 d. Apr 1985
12
Judy Neu
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4.1]
12
Douglas Neu
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4.2]
12
Gene Neu
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4.3]
12
Betty Neu
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4.4]
b. 1933 d. 6 Feb 2008
12
Nancy Neu
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4.5]
b. 31 Dec 1938 d. 1 Jan 2013
11
Ruth Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.5]
b. 10 Aug 1910 d. 24 Sep 1910
11
Hazel Marion Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.6]
Carroll Basil West
b. 7 Dec 1915 d. 22 Jan 1983
12
Barbara Jean West
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.6.1]
11
Theodore Edward Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.7]
b. 23 Jul 1920 d. Nov 1984
Edna Unknown
b. 29 Oct 1920 d. 25 Aug 2000
12
Roy Edward Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.7.1]
10
Dorcas Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. Jan 1894
+
H. T. Leonard
10
Mary Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. Apr 1898
+
Ray Moore
10
Clarence Fuller Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 6 Sep 1903 d. May 1966
Georgianna Gallinger
b. 5 Jul 1907
11
John Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 21 Oct 1934 d. 22 Oct 1934
9
Emmagene Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 21 Oct 1866 d. 22 Jan 1946
Wiliam Vernier Whitford
b. 4 Apr 1864 d. 7 Dec 1941
10
Howard E. Whitford
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 17 Sep 1888 d. 2 Mar 1963
Bertha Lohnes
b. 21 Feb 1890 d. 15 Sep 1958
11
William L. Whitford
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.1]
b. 16 Dec 1916 d. 5 Aug 1956
10
Vivla Whitford
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 1906
9
Eva May Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. Sep 1872 d. 1 Jan 1931
Charles Aaron Fuller
b. 24 Oct 1851 d. 25 Dec 1927
10
Mollie E. Fuller
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 22 May 1889 d. 18 Nov 1977
Unknown Pierce
11
Roy Pierce
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.1]
10
James Dyer Fuller
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 13 May 1891 d. 28 Mar 1953
11
Ella Fuller
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.1]
11
William Fuller
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2]
9
George William Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. Mar 1880
9
Frank Earl Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 18 Nov 1883 d. 6 May 1947
Angie Inez Cleveland
b. 6 Jul 1887 d. 16 Mar 1962
10
James Ira Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 17 Mar 1908 d. 24 May 1990
+
Ada Louise Wilber
b. 7 Mar 1907 d. 19 Apr 1990
10
Lynn Howard Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 7 Nov 1909 d. 20 May 1979
Maxine Shelah Hitchcock
b. 4 Feb 1909 d. 8 Mar 2008
11
Aileen Helen Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.1]
b. 21 Nov 1928 d. 7 Dec 2011
Charles Joseph Pizon
b. 4 Jul 1923 d. 5 Aug 1997
12
David Charles Pizon
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.1.1]
[
=>
]
12
Dotty Ann Pizon
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.1.2]
11
Alma Elaine Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.2]
b. 27 Nov 1933 d. 27 Nov 2006
+
Robert Blechinger
11
Ronald Lynn Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.3]
b. 17 Dec 1936 d. 8 May 2003
Nancy Southard
b. 1 Jan 1947 d. 11 Feb 2018
12
Scott Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.3.1]
12
Rick Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.3.2]
12
Adam Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.3.3]
12
Grant L. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.3.4]
12
Keish Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.3.5]
12
Kelly M. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.3.6]
10
Harrison Newton Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3]
b. 11 May 1911 d. 1 Nov 1977
Grace C. Potter
b. 9 Nov 1914 d. 3 Mar 1974
11
Nancy Pearl Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.1]
b. 1935 d. 10 Mar 1947
Ruth Ellen Davis
b. 16 Apr 1917 d. 2 Aug 1991
11
Carol Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.2]
+
Unknown Boswell
11
Patricia R. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.3]
David F. Ingraham
b. 23 Aug 1941 d. 12 Jan 2002
12
Kristine Ingraham
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.3.1]
12
Garret Ingraham
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.3.2]
11
Janet Marion Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.4]
b. 15 Feb 1950 d. 11 Oct 1965
11
Donna Nancy Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.5]
George Irving Ballou
12
Ryan George Ballou
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.5.1]
12
Corey Scott Ballou
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.5.2]
[
=>
]
10
Frank Earl Sanderson, Jr
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 26 Apr 1912 d. 20 Nov 1975
Lucy Margaret Potter
b. 25 Jul 1916 d. 30 Jul 1996
11
Baby Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.1]
11
Frank Earl Sanderson, Jr
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.2]
b. 15 Jun 1934 d. 26 Mar 2016
Marilyn Janice Maitland
b. 13 Apr 1940 d. 9 Aug 2024
12
Bruce W. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.2.1]
12
Janice M. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.2.2]
12
Linda Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.2.3]
11
Elizabeth Anne Betty Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.3]
b. 19 Jun 1936 d. 10 Jan 1944
11
Judith Eva Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.4]
b. 2 Apr 1945 d. 4 Jan 2006
David Daugherty
12
Tracy Daugherty
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.4.1]
12
Erin Daugherty
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.4.2]
11
James Edward Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.5]
b. 20 Sep 1946 d. 3 Aug 2021
Bonnie Jane Bettinger
12
Betha Ann Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.1]
+
Carol Ann Duby
Suzanne Kubala
12
Tammy Suzanne Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.2]
Mary Leillia Kohler
12
Thomas Frank Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.3]
12
Dawn Lucy Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.4]
12
Libby Ann Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.5]
11
Larry George Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.6]
Margaret Elizabeth Stephenson
12
Laureen Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.6.1]
12
Larry Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.6.2]
12
William Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.6.3]
11
Cindy Lou Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.7]
+
David Love
10
Grant Lee Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.5]
b. 19 Dec 1927 d. 12 May 1949
Marjorie J. Flint
b. 30 Jun 1928 d. 21 Apr 2011
11
Grant Lee Sanderson Delong
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.5.1]
+
Rita Unknown
10
John William Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6]
b. 11 Apr 1930 d. 16 Aug 2015
+
Barbara Kennedy Nelson
Beverly Jean Maitland
b. 6 Sep 1933 d. 28 Mar 2016
11
Dianne Jean Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.1]
Gary Lou Dawley
12
Rebecca Jean Dawley
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.1.1]
[
=>
]
12
Angela Louise Dawley
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.1.2]
[
=>
]
12
Bradley Jay Dawley
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.1.3]
[
=>
]
+
Stephen George Wilson
11
Douglas John Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.2]
+
Linda Elaine Green
Laurie Marie Ladouceur
12
Gabriel Douglas Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.2.1]
[
=>
]
11
Delores Jane Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.3]
Frank Lamont Hilliker
12
Jessie Jane Hilliker
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.3.1]
12
Jonathan Hilliker
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.3.2]
[
=>
]
11
Dennis James Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.4]
b. 31 Jan 1958 d. 11 Jan 2016
Sherry Lynn Spicer
12
Eric James Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.4.1]
[
=>
]
12
Christopher J. Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.4.2]
11
Danny Joe Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.5]
Diane Richardson
12
Konor Joseph Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.5.1]
12
Samantha Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.5.2]
9
Burton Briggs Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 19 Sep 1886 d. 24 Jan 1961
Mabel Belle Brown
b. 11 Nov 1893 d. 1 Nov 1973
10
Iva Belle Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.1]
b. 8 Nov 1913 d. 21 Apr 1978
+
Ebert E. Dillabough