Stewarts Genealogy
First Name
Last Name
[Advanced Search]
[Surnames]
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Share
Print
Bookmark
Agnes Stone
1557 - 1616 (59 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Agnes Stone
[1]
b. 1557 d. 15 Jan 1616
Richard Adams
b. 1552 d. 19 Mar 1603
2
Henry Adams
[1.1]
b. 21 Jan 1582 d. 8 Oct 1646
Edith Squire
b. Abt 1587 d. 21 Jan 1672
3
Edward Adams
[1.1.1]
b. 19 Apr 1629 d. 12 Nov 1716
+
Lydia Penniman
b. 22 Feb 1634/35 d. 3 Mar 1675/76
Lydia Rockwood
b. Abt 1631 d. Abt 1676
4
John Adams
[1.1.1.1]
b. 18 Feb 1657
Deborah Partridge
b. Abt 1657
5
Edward Adams
[1.1.1.1.1]
b. 13 Jan 1682 d. 22 Sep 1742
Rachel Sanders
b. Abt 1683
6
Edward Adams
[1.1.1.1.1.1]
b. 1 Mar 1707 d. 1793
Deliverance Trott
b. Abt 1708
7
Edward Adams
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 16 Mar 1738 d. Nov 1825
Dorothy Spear
b. Abt 1740 d. 1802
8
Betsey Adams
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1779 d. 1843
Joshua Hollis
b. 1773 d. 1850
9
David Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 12 Sep 1801 d. 1893
Laura Williams
d. 5 Aug 1863
10
Celestia Marion Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1 Apr 1832 d. 2 Oct 1914
Hezikiah Ezra Mattison
b. Abt 1832 d. 14 Feb 1899
11
Anice Sophia Matteson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 2 Jul 1859 d. 28 Mar 1920
Seymour J. Smith
12
Stanley M. Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 19 Apr 1885 d. 10 Aug 1939 [
=>
]
12
Mabel Estella Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 16 May 1887 d. 29 Mar 1888
12
Alburn Leroy Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 3 Oct 1892 [
=>
]
11
Laura Estella Mattison
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 18 Nov 1864 d. 16 May 1928
Charles Levit Smith
b. 9 Feb 1854 d. 6 Jun 1934
12
Laura Marian Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 23 Nov 1886
12
Ada Loretta Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 2 Oct 1889 d. 5 Feb 1964 [
=>
]
11
David Benjamin Mattison
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 25 Oct 1872 d. 29 Jul 1932
+
Elizabeth Betsey Montondo
b. 31 Oct 1861 d. 26 Oct 1948
10
John Nelson Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1834 d. 27 Jun 1865
+
Martha Glae
9
Lucy Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1803
9
Asenath Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 20 Jul 1806 d. 17 Apr 1887
Matthew Henderson Presler
b. 26 Aug 1808 d. 24 Oct 1898
10
Betsy Presler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 12 Oct 1831 d. Nov 1831
10
Josiah Presler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 10 Apr 1833 d. 3 Jul 1833
10
William Hollis Presler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 25 May 1836 d. 14 Jun 1911
Theodosia Cogswell
b. 14 Apr 1840 d. 7 May 1866
11
Infant Twin Presler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 16 Nov 1860 d. 28 Dec 1860
11
Infant Twin Presler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 16 Nov 1860 d. 28 Dec 1860
11
Flora A Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 7 Mar 1863 d. 6 Mar 1932
Ellen Elizabeth Halsey
b. 30 Jul 1845 d. 10 Feb 1920
11
Fred Lincoln Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 22 Oct 1865 d. 31 Jul 1924
11
Clara Ellen Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 18 Sep 1872 d. 24 Jan 1951
John Edwin Delong
b. 22 Jan 1867 d. 3 Oct 1924
12
Anna Elizabeth Delong
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.1]
b. 13 Feb 1895 d. 10 Jan 1994 [
=>
]
12
Roy E Delong
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.2]
b. Abt 1896
12
Blanche E Delong
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.3]
b. Abt 1899
12
Earl Vincent Delong
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.4]
b. 6 Mar 1903 d. 25 Nov 1985 [
=>
]
12
Hayden F Delong
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.5]
b. Abt 1904
12
Raymond J Delong
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.6]
b. Abt 1909
11
Arthur William Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6]
b. 19 Sep 1874 d. 13 Sep 1962
Sarah Elizabeth Winsor
b. 15 Jan 1877 d. 18 Mar 1964
12
Mary R. Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.1]
b. 6 Mar 1902 d. 18 Apr 1986
12
Lee Henry Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.2]
b. 21 May 1904 d. 8 May 2001
12
Ellen E Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.3]
b. 12 Jan 1915 d. 27 Jan 2005
11
Mary Alice Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7]
b. 3 Jan 1877 d. 9 Jan 1970
George Henry Waggoner, Jr.
b. 26 Jan 1875 d. 17 Jun 1957
12
Marguerite Ellen Waggoner
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1]
b. 3 May 1903 d. 22 Nov 1960 [
=>
]
12
Merril Victor Waggoner
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2]
b. 19 Jan 1915 d. 28 Nov 1982 [
=>
]
12
Arthur F. Waggoner
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3]
b. 23 Aug 1919 d. 9 Jan 2016 [
=>
]
11
Anna M. Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.8]
b. 24 May 1883 d. 16 Feb 1914
11
Vernon Lee Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.9]
b. 11 Apr 1890 d. 11 Dec 1890
10
Leander Cole Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 10 Nov 1838 d. 25 Jun 1901
Ermina Presley
b. 16 Jun 1837 d. 14 Mar 1928
11
Charles Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
11
Nellie Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2]
11
Angie Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
11
Lucy Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4]
11
Clara Ermina Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 22 Aug 1866 d. 27 Mar 1933
10
Margaret Ann Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 3 Mar 1842 d. 2 Nov 1863
10
Lydia J. Presler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. Abt 28 Jul 1846 d. 1885
10
Mary Lucy Presley
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 18 Nov 1849 d. 8 Apr 1938
Charles Paddock
b. 6 Mar 1847 d. 29 Jul 1926
11
Clinton Ward Paddock
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1]
b. 10 Jul 1892 d. 23 Jan 1979
Florence Belle Lighthall
b. 31 Oct 1892 d. 29 Mar 1967
12
Mildred Florence Paddock
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1.1]
b. 6 Aug 1911 d. 24 Apr 2001 [
=>
]
12
Bertha Mae Paddock
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1.2]
b. 1914
12
Mary Josephine Paddock
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1.3]
b. 2 May 1916 d. 29 Oct 1930
9
John Adams Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 10 Jul 1809 d. 25 May 1898
Ann Tuttle
b. 12 Sep 1813 d. 1 Apr 1880
10
William C. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 16 Apr 1836 d. 30 Aug 1862
+
Alice Mary Parker
10
John Joshua Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 29 Jan 1841 d. 10 Jan 1936
Annette Howlett
b. 26 Mar 1844 d. 29 Jul 1919
11
Deforest J. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 23 Jan 1871 d. 1 Oct 1937
Angie Hanna Widrig
b. 26 Oct 1873 d. 4 Apr 1928
12
Lawrence Widrig Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 21 Jul 1897 d. 14 May 1982 [
=>
]
12
Berine A Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. Abt 1901
12
Angie Louise Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 20 Jan 1901 d. 3 Jan 1990
12
Deforest J. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.4]
+
Lula Ward
b. 10 Sep 1881 d. 4 Jul 1952
11
Leroy Frank Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 30 Apr 1871 d. 13 Jul 1946
Florence A. Tift
b. Mar 1873
12
Harwood Leroy Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.1]
11
Starr C. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 18 Aug 1879 d. 10 Sep 1934
Ora Zufelt
b. 1877 d. 1963
12
John Adams Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.1]
12
Frances Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2]
+
Elizabeth Calkins
b. Abt 1845
+
Alice Proctor Blodgett
10
Carroll Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 25 Oct 1845 d. 1 Feb 1916
Marcia Salisbury
b. Abt 1846 d. 1906
11
William C. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 1 Jan 1871 d. 22 Mar 1948
+
Flora Hathaway
+
Mary Lawton
b. 1849
10
Gilbert W. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 1 Jul 1848 d. 1914
Flora Arlette Hinman
b. Sep 1846
11
Anna J. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
+
Unknown Hart
10
Deforest J. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 23 Jan 1871 d. 1 Oct 1937
Angie Hanna Widrig
b. 26 Oct 1873 d. 4 Apr 1928
11
Lawrence Widrig Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 21 Jul 1897 d. 14 May 1982
Ina Adelle White
b. 6 Dec 1895 d. 11 Oct 1966
12
John Lawrence Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.1.1]
b. Abt Jan 1928 d. Abt 24 Dec 1999
12
Margaret Ann Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.1.2]
[
=>
]
11
Berine A Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.2]
b. Abt 1901
11
Angie Louise Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.3]
b. 20 Jan 1901 d. 3 Jan 1990
+
Harvey Robbins
11
Deforest J. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.4]
+
Lula Ward
b. 10 Sep 1881 d. 4 Jul 1952
9
Samuel Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 22 Jun 1812 d. 1858
Lucy Ann Crocker
b. 15 Jul 1814 d. 7 Jan 1909
10
Gardner Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 1842 d. 20 Jun 1909
10
Delano David Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 1843
Harriet Louise Barber
11
Lena Belle Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.1]
Henry George Hubbard
12
Don Delano Hubbard
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.1.1]
[
=>
]
11
Chauncey Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.2]
11
Bessie Louise Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.3]
11
Iva May Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.4]
b. 1885
+
Lawrence Everett Clark
b. 1888
10
Mary Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.3]
b. 21 Aug 1847 d. Aft 1950
+
William Pitt Ackley
b. 18 Aug 1840 d. Feb 1912
10
Wesley Monroe Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4]
b. 22 Oct 1849 d. 15 Apr 1924
Maryette Almira Tryon
b. 14 Feb 1852 d. 20 Sep 1942
11
Ida May Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1]
b. 28 Aug 1872 d. 29 Nov 1941
+
Henry Philbrick
b. Abt 1870
George E. Tryon
b. Dec 1865 d. 1901
12
Ray Wesley Tryon
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1.1]
12
Florence Leona Tryon
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1.2]
b. 27 May 1892
12
Gladys Marie Tryon
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1.3]
b. 1898 [
=>
]
+
Harry Newton Philbrick
b. 4 Feb 1882 d. 26 Jan 1952
11
Donald Delano Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.2]
b. 1879 d. 1912
11
Bessie May Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.3]
b. 1884 d. 22 Nov 1976
10
Robert W. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.5]
b. Oct 1852
11
Bessie M. Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.1]
10
Albert Samuel Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.6]
b. 1855 d. 1882
9
William Howard Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 17 Oct 1815 d. 1895
Maria Margaret Rima
b. 24 Nov 1818 d. Sep 1863
10
Esther Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 28 Dec 1839 d. 28 Jul 1926
+
George L. Stevens
10
Malcom Leroy Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 22 Jul 1841 d. 18 Aug 1927
Esther Eldula Bentley
b. 20 Jul 1846 d. 30 Oct 1925
11
Harriet Seymour Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 16 Jan 1870 d. 3 Jan 1959
+
Herbert William Damon
b. 30 May 1863 d. 21 Dec 1954
11
William Howard Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. 8 Jan 1876 d. 1933
+
Charlotte May Fish
b. 12 Aug 1869 d. 26 Mar 1938
11
Malcom Leroy Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.3]
b. 30 Mar 1882 d. 1883
11
Norman Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.4]
b. Abt Sep 1886 d. 25 Mar 1901
10
Harriet Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3]
b. Abt 1843 d. 1863
10
Henry Albert Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 25 May 1845 d. 8 Apr 1925
Delila A. Lattimer
b. 17 Apr 1852 d. 2 Oct 1917
11
Frank William Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.1]
b. 27 Feb 1871 d. 2 Jul 1948
Ruth A. Wardwell
b. 1890
12
Clarence Wardwell Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.1.1]
b. 17 Jul 1914 d. Jul 1992 [
=>
]
12
Lila Eleanor Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.1.2]
12
Beverly Jane Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.1.3]
11
George Lewis Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2]
b. 11 Jun 1876 d. Jul 1970
11
Earl Jay Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3]
b. 27 Sep 1879 d. 16 Jan 1949
+
Ethel H. Hewitt
b. 1886
11
Fred Henry Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.4]
b. 22 Dec 1884 d. 17 Jul 1965
May Maude Dight
b. 1894 d. 31 Oct 1967
12
Frederick Dean Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.4.1]
12
Marcia Jean Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.4.2]
12
Marjorie Joyce Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.4.3]
b. 6 Sep 1932 d. 6 Nov 2022
10
Theron Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5]
b. Abt 1846
Lois Ellen Unknown
11
Williard Weir Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 1884 d. 4 Feb 1889
10
Sarah Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.6]
b. Abt 1847
10
Jay Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.7]
b. Abt 1849
10
Sylvia Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.8]
b. Abt 1850
10
Howard Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.9]
b. Abt 1851 d. 1887
10
Sarah Cornelia Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.10]
b. 26 Jul 1851 d. 21 Apr 1916
Henry John Stowell
b. 10 May 1831 d. 1 Aug 1897
11
Grace Rosella Stowell
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.1]
b. 5 Jul 1877 d. 7 Jul 1948
+
Donald Alonzo Hilton
b. 12 Aug 1857 d. 16 Sep 1933
+
Lewis Chapin Samson
b. 1 Sep 1846 d. 20 Sep 1909
10
Jennie Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.11]
b. Abt 1852
10
William Howard Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.12]
b. 1855 d. 1863
9
Gilbert Hollis
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1818 d. 1848
+
Unknown Widow Green
+
Abigail Craft Ruggles
+
Sarah Taylor
Mary Alexander
b. 1584
3
Edward Adams
[1.1.2]
b. 19 Apr 1629 d. 12 Nov 1716
+
Lydia Penniman
b. 22 Feb 1634/35 d. 3 Mar 1675/76
Lydia Rockwood
b. Abt 1631 d. Abt 1676
4
John Adams
[1.1.2.1]
b. 18 Feb 1657
Deborah Partridge
b. Abt 1657
5
Edward Adams
[1.1.2.1.1]
b. 13 Jan 1682 d. 22 Sep 1742
Rachel Sanders
b. Abt 1683
6
Edward Adams
[1.1.2.1.1.1]
b. 1 Mar 1707 d. 1793
Deliverance Trott
b. Abt 1708
7
Edward Adams
[1.1.2.1.1.1.1]
b. 16 Mar 1738 d. Nov 1825
Dorothy Spear
b. Abt 1740 d. 1802
8
Betsey Adams
[1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 1779 d. 1843
Joshua Hollis
b. 1773 d. 1850
9
David Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 12 Sep 1801 d. 1893
Laura Williams
d. 5 Aug 1863
10
Celestia Marion Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1 Apr 1832 d. 2 Oct 1914
Hezikiah Ezra Mattison
b. Abt 1832 d. 14 Feb 1899
11
Anice Sophia Matteson
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 2 Jul 1859 d. 28 Mar 1920
Seymour J. Smith
12
Stanley M. Smith
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 19 Apr 1885 d. 10 Aug 1939 [
=>
]
12
Mabel Estella Smith
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 16 May 1887 d. 29 Mar 1888
12
Alburn Leroy Smith
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 3 Oct 1892 [
=>
]
11
Laura Estella Mattison
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 18 Nov 1864 d. 16 May 1928
Charles Levit Smith
b. 9 Feb 1854 d. 6 Jun 1934
12
Laura Marian Smith
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 23 Nov 1886
12
Ada Loretta Smith
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 2 Oct 1889 d. 5 Feb 1964 [
=>
]
11
David Benjamin Mattison
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 25 Oct 1872 d. 29 Jul 1932
+
Elizabeth Betsey Montondo
b. 31 Oct 1861 d. 26 Oct 1948
10
John Nelson Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1834 d. 27 Jun 1865
+
Martha Glae
9
Lucy Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.2]
b. 1803
9
Asenath Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.3]
b. 20 Jul 1806 d. 17 Apr 1887
Matthew Henderson Presler
b. 26 Aug 1808 d. 24 Oct 1898
10
Betsy Presler
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.1]
b. 12 Oct 1831 d. Nov 1831
10
Josiah Presler
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.2]
b. 10 Apr 1833 d. 3 Jul 1833
10
William Hollis Presler
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3]
b. 25 May 1836 d. 14 Jun 1911
Theodosia Cogswell
b. 14 Apr 1840 d. 7 May 1866
11
Infant Twin Presler
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 16 Nov 1860 d. 28 Dec 1860
11
Infant Twin Presler
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 16 Nov 1860 d. 28 Dec 1860
11
Flora A Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 7 Mar 1863 d. 6 Mar 1932
Ellen Elizabeth Halsey
b. 30 Jul 1845 d. 10 Feb 1920
11
Fred Lincoln Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 22 Oct 1865 d. 31 Jul 1924
11
Clara Ellen Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 18 Sep 1872 d. 24 Jan 1951
John Edwin Delong
b. 22 Jan 1867 d. 3 Oct 1924
12
Anna Elizabeth Delong
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.5.1]
b. 13 Feb 1895 d. 10 Jan 1994 [
=>
]
12
Roy E Delong
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.5.2]
b. Abt 1896
12
Blanche E Delong
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.5.3]
b. Abt 1899
12
Earl Vincent Delong
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.5.4]
b. 6 Mar 1903 d. 25 Nov 1985 [
=>
]
12
Hayden F Delong
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.5.5]
b. Abt 1904
12
Raymond J Delong
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.5.6]
b. Abt 1909
11
Arthur William Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.6]
b. 19 Sep 1874 d. 13 Sep 1962
Sarah Elizabeth Winsor
b. 15 Jan 1877 d. 18 Mar 1964
12
Mary R. Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.6.1]
b. 6 Mar 1902 d. 18 Apr 1986
12
Lee Henry Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.6.2]
b. 21 May 1904 d. 8 May 2001
12
Ellen E Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.6.3]
b. 12 Jan 1915 d. 27 Jan 2005
11
Mary Alice Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.7]
b. 3 Jan 1877 d. 9 Jan 1970
George Henry Waggoner, Jr.
b. 26 Jan 1875 d. 17 Jun 1957
12
Marguerite Ellen Waggoner
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.7.1]
b. 3 May 1903 d. 22 Nov 1960 [
=>
]
12
Merril Victor Waggoner
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.7.2]
b. 19 Jan 1915 d. 28 Nov 1982 [
=>
]
12
Arthur F. Waggoner
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.7.3]
b. 23 Aug 1919 d. 9 Jan 2016 [
=>
]
11
Anna M. Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.8]
b. 24 May 1883 d. 16 Feb 1914
11
Vernon Lee Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.9]
b. 11 Apr 1890 d. 11 Dec 1890
10
Leander Cole Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.4]
b. 10 Nov 1838 d. 25 Jun 1901
Ermina Presley
b. 16 Jun 1837 d. 14 Mar 1928
11
Charles Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.4.1]
11
Nellie Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.4.2]
11
Angie Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.4.3]
11
Lucy Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.4.4]
11
Clara Ermina Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 22 Aug 1866 d. 27 Mar 1933
10
Margaret Ann Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.5]
b. 3 Mar 1842 d. 2 Nov 1863
10
Lydia J. Presler
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.6]
b. Abt 28 Jul 1846 d. 1885
10
Mary Lucy Presley
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.7]
b. 18 Nov 1849 d. 8 Apr 1938
Charles Paddock
b. 6 Mar 1847 d. 29 Jul 1926
11
Clinton Ward Paddock
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.7.1]
b. 10 Jul 1892 d. 23 Jan 1979
Florence Belle Lighthall
b. 31 Oct 1892 d. 29 Mar 1967
12
Mildred Florence Paddock
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.7.1.1]
b. 6 Aug 1911 d. 24 Apr 2001 [
=>
]
12
Bertha Mae Paddock
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.7.1.2]
b. 1914
12
Mary Josephine Paddock
[1.1.2.1.1.1.1.1.3.7.1.3]
b. 2 May 1916 d. 29 Oct 1930
9
John Adams Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4]
b. 10 Jul 1809 d. 25 May 1898
Ann Tuttle
b. 12 Sep 1813 d. 1 Apr 1880
10
William C. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.1]
b. 16 Apr 1836 d. 30 Aug 1862
+
Alice Mary Parker
10
John Joshua Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2]
b. 29 Jan 1841 d. 10 Jan 1936
Annette Howlett
b. 26 Mar 1844 d. 29 Jul 1919
11
Deforest J. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 23 Jan 1871 d. 1 Oct 1937
Angie Hanna Widrig
b. 26 Oct 1873 d. 4 Apr 1928
12
Lawrence Widrig Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 21 Jul 1897 d. 14 May 1982 [
=>
]
12
Berine A Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. Abt 1901
12
Angie Louise Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 20 Jan 1901 d. 3 Jan 1990
12
Deforest J. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.4]
+
Lula Ward
b. 10 Sep 1881 d. 4 Jul 1952
11
Leroy Frank Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 30 Apr 1871 d. 13 Jul 1946
Florence A. Tift
b. Mar 1873
12
Harwood Leroy Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.2.1]
11
Starr C. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 18 Aug 1879 d. 10 Sep 1934
Ora Zufelt
b. 1877 d. 1963
12
John Adams Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.3.1]
12
Frances Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.3.2]
+
Elizabeth Calkins
b. Abt 1845
+
Alice Proctor Blodgett
10
Carroll Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.3]
b. 25 Oct 1845 d. 1 Feb 1916
Marcia Salisbury
b. Abt 1846 d. 1906
11
William C. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 1 Jan 1871 d. 22 Mar 1948
+
Flora Hathaway
+
Mary Lawton
b. 1849
10
Gilbert W. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.4]
b. 1 Jul 1848 d. 1914
Flora Arlette Hinman
b. Sep 1846
11
Anna J. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.4.1]
+
Unknown Hart
10
Deforest J. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.5]
b. 23 Jan 1871 d. 1 Oct 1937
Angie Hanna Widrig
b. 26 Oct 1873 d. 4 Apr 1928
11
Lawrence Widrig Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 21 Jul 1897 d. 14 May 1982
Ina Adelle White
b. 6 Dec 1895 d. 11 Oct 1966
12
John Lawrence Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1]
b. Abt Jan 1928 d. Abt 24 Dec 1999
12
Margaret Ann Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.2]
[
=>
]
11
Berine A Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.2]
b. Abt 1901
11
Angie Louise Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.3]
b. 20 Jan 1901 d. 3 Jan 1990
+
Harvey Robbins
11
Deforest J. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.4]
+
Lula Ward
b. 10 Sep 1881 d. 4 Jul 1952
9
Samuel Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5]
b. 22 Jun 1812 d. 1858
Lucy Ann Crocker
b. 15 Jul 1814 d. 7 Jan 1909
10
Gardner Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.1]
b. 1842 d. 20 Jun 1909
10
Delano David Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.2]
b. 1843
Harriet Louise Barber
11
Lena Belle Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.2.1]
Henry George Hubbard
12
Don Delano Hubbard
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.1]
[
=>
]
11
Chauncey Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.2.2]
11
Bessie Louise Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.2.3]
11
Iva May Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.2.4]
b. 1885
+
Lawrence Everett Clark
b. 1888
10
Mary Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.3]
b. 21 Aug 1847 d. Aft 1950
+
William Pitt Ackley
b. 18 Aug 1840 d. Feb 1912
10
Wesley Monroe Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.4]
b. 22 Oct 1849 d. 15 Apr 1924
Maryette Almira Tryon
b. 14 Feb 1852 d. 20 Sep 1942
11
Ida May Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.4.1]
b. 28 Aug 1872 d. 29 Nov 1941
+
Henry Philbrick
b. Abt 1870
George E. Tryon
b. Dec 1865 d. 1901
12
Ray Wesley Tryon
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.4.1.1]
12
Florence Leona Tryon
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.4.1.2]
b. 27 May 1892
12
Gladys Marie Tryon
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.4.1.3]
b. 1898 [
=>
]
+
Harry Newton Philbrick
b. 4 Feb 1882 d. 26 Jan 1952
11
Donald Delano Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.4.2]
b. 1879 d. 1912
11
Bessie May Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.4.3]
b. 1884 d. 22 Nov 1976
10
Robert W. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.5]
b. Oct 1852
11
Bessie M. Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.5.1]
10
Albert Samuel Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.5.6]
b. 1855 d. 1882
9
William Howard Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6]
b. 17 Oct 1815 d. 1895
Maria Margaret Rima
b. 24 Nov 1818 d. Sep 1863
10
Esther Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.1]
b. 28 Dec 1839 d. 28 Jul 1926
+
George L. Stevens
10
Malcom Leroy Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.2]
b. 22 Jul 1841 d. 18 Aug 1927
Esther Eldula Bentley
b. 20 Jul 1846 d. 30 Oct 1925
11
Harriet Seymour Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 16 Jan 1870 d. 3 Jan 1959
+
Herbert William Damon
b. 30 May 1863 d. 21 Dec 1954
11
William Howard Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. 8 Jan 1876 d. 1933
+
Charlotte May Fish
b. 12 Aug 1869 d. 26 Mar 1938
11
Malcom Leroy Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.2.3]
b. 30 Mar 1882 d. 1883
11
Norman Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.2.4]
b. Abt Sep 1886 d. 25 Mar 1901
10
Harriet Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.3]
b. Abt 1843 d. 1863
10
Henry Albert Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4]
b. 25 May 1845 d. 8 Apr 1925
Delila A. Lattimer
b. 17 Apr 1852 d. 2 Oct 1917
11
Frank William Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.1]
b. 27 Feb 1871 d. 2 Jul 1948
Ruth A. Wardwell
b. 1890
12
Clarence Wardwell Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.1.1]
b. 17 Jul 1914 d. Jul 1992 [
=>
]
12
Lila Eleanor Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.1.2]
12
Beverly Jane Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.1.3]
11
George Lewis Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.2]
b. 11 Jun 1876 d. Jul 1970
11
Earl Jay Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.3]
b. 27 Sep 1879 d. 16 Jan 1949
+
Ethel H. Hewitt
b. 1886
11
Fred Henry Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.4]
b. 22 Dec 1884 d. 17 Jul 1965
May Maude Dight
b. 1894 d. 31 Oct 1967
12
Frederick Dean Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.4.1]
12
Marcia Jean Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.4.2]
12
Marjorie Joyce Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.4.4.3]
b. 6 Sep 1932 d. 6 Nov 2022
10
Theron Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.5]
b. Abt 1846
Lois Ellen Unknown
11
Williard Weir Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 1884 d. 4 Feb 1889
10
Sarah Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.6]
b. Abt 1847
10
Jay Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.7]
b. Abt 1849
10
Sylvia Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.8]
b. Abt 1850
10
Howard Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.9]
b. Abt 1851 d. 1887
10
Sarah Cornelia Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.10]
b. 26 Jul 1851 d. 21 Apr 1916
Henry John Stowell
b. 10 May 1831 d. 1 Aug 1897
11
Grace Rosella Stowell
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.10.1]
b. 5 Jul 1877 d. 7 Jul 1948
+
Donald Alonzo Hilton
b. 12 Aug 1857 d. 16 Sep 1933
+
Lewis Chapin Samson
b. 1 Sep 1846 d. 20 Sep 1909
10
Jennie Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.11]
b. Abt 1852
10
William Howard Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.6.12]
b. 1855 d. 1863
9
Gilbert Hollis
[1.1.2.1.1.1.1.1.7]
b. 1818 d. 1848
+
Unknown Widow Green
+
Abigail Craft Ruggles
+
Sarah Taylor