Stewarts Genealogy
First Name
Last Name
[Advanced Search]
[Surnames]
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Share
Print
Bookmark
Margaret Morse
1555 - Aft 1591 (> 37 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Margaret Morse
[1]
b. 1555 d. Aft 1591
Thomas Thurston
b. 1555 d. Aft 1591
2
Julian Thurston
[1.1]
b. Bef 26 Sep 1576 d. 3 Oct 1611
2
Thomas Thurston
[1.2]
b. 1578 d. 1 Apr 1626
Grace Utting
b. 1587 d. 13 Feb 1638
3
John Thurston
[1.2.1]
b. 13 Jan 1611 d. 1 Nov 1685
Margaret Buck
b. 1605 d. 9 May 1662
4
Thomas Thurston
[1.2.1.1]
b. 4 Aug 1633 d. 20 May 1704
Sarah Thaxter
b. 1635 d. 1 Sep 1678
5
John Thurston
[1.2.1.1.1]
b. 4 Mar 1656 d. 24 Nov 1711
Hannah Cary
b. 30 Apr 1661 d. 1718
6
David Thurston
[1.2.1.1.1.1]
b. 2 Nov 1689 d. 31 May 1759
Mercy Cary
b. 28 Jan 1686 d. 18 Nov 1725
7
John Thurston
[1.2.1.1.1.1.1]
b. 22 May 1714 d. Jun 1767
Sabary Seabury Saberah Stodder
b. 8 Sep 1715 d. 26 Mar 1764
8
John Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 9 Jul 1736
8
Job Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2]
b. 27 Jan 1737 d. 22 Sep 1819
Dorcas Garnsey
b. 23 Feb 1744 d. 1835
9
Job Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1]
b. 1770 d. 1820
Hannah Watson
b. 23 Jul 1776
10
Elizabeth Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. Abt 1790
+
John A. Sweet, Jr.
10
John Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 31 Oct 1795 d. 7 Aug 1854
Hannah Winterbotham
b. 18 Sep 1799 d. 9 Apr 1869
11
Permelia Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.1]
b. Abt 1822 d. 18 Feb 1902
Samuel Waterman
b. Abt 1819 d. 20 Mar 1878
12
Emmett T Waterman
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1]
b. Dec 1848 d. 29 Jul 1914
12
Zephaniah Waterman
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2]
b. Abt 1850
12
Joseph Henry Waterman
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.1.3]
b. Abt 1853
12
Josephine Waterman
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.1.4]
b. Mar 1853
12
Alfred K Waterman
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.1.5]
b. Abt 1863
11
John Emmett Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2]
b. Nov 1829 d. 1911
Sarah Lucy Meese
b. Aug 1867 d. Abt 1954
12
Emmett Lansing Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.1]
b. 24 Sep 1879
12
Tinny Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.2]
b. Abt 1892
12
Ninnah M McConnell
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.3]
b. Abt 1894
12
Myra Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.4]
b. Sep 1894
12
Nina Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.5]
b. Sep 1894
12
Sam Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.6]
b. Abt 1896
12
Rosa Lee Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.7]
b. 22 Feb 1898 d. 13 Sep 1974 [
=>
]
12
Agnes Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.8]
b. Abt 1902 d. Bef 1970
12
Agnes Cora Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.9]
b. 2 Apr 1903 d. Sep 1977 [
=>
]
12
U S Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.10]
b. Abt 1905
9
Stephen Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.2]
b. Abt 1772
9
Rhoda Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.3]
b. Abt 1774
9
Ebenezer Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.4]
b. Abt 1776
9
Daniel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5]
b. 1777 d. 1820
Mary Polly Edson
b. 24 Mar 1778 d. 8 Sep 1867
10
Hiram Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1]
b. 1802 d. 29 Sep 1883
Amy Almira Hamilton
b. 1805 d. 14 Jul 1882
11
John E. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.1]
b. 1827 d. 1898
Maria L. Shepard
b. 1829
12
George Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.1.1]
b. 1849/1850
12
Effie F. Mary Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.1.2]
b. 1853/1856
12
John Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.1.3]
b. 1858/1859
12
Elmer E Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.1.4]
b. May 1865 [
=>
]
12
Pearl M. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.1.5]
b. 1863/1869
11
Ruth Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.2]
b. 1828 d. 18 Jan 1902
11
Hiram Edwin Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3]
b. 1834 d. 21 Aug 1881
Diana Babcock
b. Aug 1839 d. 6 Feb 1922
12
Hiram Hamilton Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.1]
b. 11 Nov 1856 d. 27 Jun 1896 [
=>
]
12
Adele Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.2]
b. Aug 1860 d. 1937 [
=>
]
12
Isabel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.3]
b. 1862 d. 3 Feb 1919
12
Zoa M. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.4]
b. 23 Sep 1865 d. 24 Jul 1923
12
Edwin O. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.5]
b. 1867 d. 1931
12
Myron B. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.6]
b. 1869
12
Fred Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.7]
b. 1869
12
Johnson D Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.8]
b. 1873 d. 1907 [
=>
]
12
Myron Benjamin Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.9]
b. 18 Jul 1873 d. 17 Nov 1937
12
Emma Gertrude Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.3.10]
b. Nov 1878 d. 18 Feb 1946
11
Edwin Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.4]
b. Abt 1835 d. Bef 1892
11
Samuel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.5]
b. Between 1836 and 1837
11
Job Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.6]
b. Between 1838 and 1839
11
Susan Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.7]
b. 1840
11
Job H. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.8]
b. 1841 d. 1875
+
Helen Unknown
b. 1851
11
Frances Melissa Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.9]
b. Jun 1843 d. 24 Nov 1902
Thomas McCann Hyland
d. 23 Feb 1919
12
Bertran E. Hyland
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.9.1]
b. 15 Sep 1874 d. 8 Jul 1941 [
=>
]
11
Flora Adele Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.10]
b. 1844 d. 15 Dec 1922
George Thomas Fearon
b. 1835 d. 1902
12
David C. Fearon
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.10.1]
12
Frederick Melvin Fearon
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.10.2]
b. 7 Sep 1867 d. 7 Dec 1928 [
=>
]
11
Zoetta Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.11]
b. 1846 d. 8 Apr 1907
Samuel J. Davis
b. Abt 1843 d. 1902
12
Albert J. Davis
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.11.1]
12
Samuel Jay Davis
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.11.2]
[
=>
]
12
Blanche Mary Davis
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.11.3]
b. 13 May 1880 d. 8 Jan 1937 [
=>
]
11
Johnson Jackson M. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.1.12]
b. 1849
10
Minerva Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2]
b. 29 Mar 1805 d. 8 Apr 1865
William N. Caswell
b. Abt 1801 d. 22 Jun 1875
11
David E Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.1]
b. 22 Nov 1832 d. 15 Apr 1903
11
Jane P Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.2]
b. Abt 1836
11
Martha Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.3]
b. Abt 1843
11
William R Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.4]
b. Abt 1845
11
Thadeus Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.5]
b. 28 Sep 1846 d. Dec 1925
Dorlesca Harriet Gould
b. 10 Oct 1846 d. 6 Sep 1922
12
Blanch Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.5.1]
12
Theodore Solomon Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.5.2]
b. 8 Oct 1868 d. 14 Nov 1936
12
Frank J. Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.5.3]
b. 29 Apr 1869 d. 28 Jun 1955 [
=>
]
12
Leverne M Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.5.4]
b. Jan 1871
12
Clifford Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.5.5]
b. 7 Sep 1872 d. 7 Mar 1944
12
Bertha Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.5.6]
b. 1877
12
Ernest Jay Caswell
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.2.5.7]
b. 15 Feb 1884 d. 13 Mar 1961
10
Marshall Jefferson Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3]
b. Abt 1806 d. 29 Sep 1883
Hannah Orcutt
b. 1805 d. 13 Feb 1864
11
Daniel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1]
b. 1827 d. 20 Feb 1903
Mary Jane Walters
b. 1836
12
Melissa Lizzie Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.1]
b. 17 Jun 1855 d. 23 Jan 1936 [
=>
]
12
Miranda Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.2]
b. 1857 d. 1904
12
Hattie Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.3]
b. 1859/1860 d. Bef 1865
12
Marshall Jefferson Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.4]
b. 9 Oct 1861 d. 24 Apr 1934 [
=>
]
12
Jessie Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.5]
b. 1865 d. Bef 1875
12
Nellie E. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.6]
b. 1869 d. 1952
12
Hannah Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.7]
b. 1871 d. 30 Jan 1918 [
=>
]
12
James Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.8]
b. 1872 d. 1909 [
=>
]
12
Arthur Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.1.9]
b. 24 Dec 1881 d. 21 Mar 1941
11
Henry Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.2]
b. Abt 1829 d. Aft 1880
Sarah Carey
12
Ida May Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.2.1]
b. 1864 d. 1931 [
=>
]
12
William Franklin Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.2.2]
b. 18 Oct 1865 d. 26 Dec 1940 [
=>
]
12
Mary Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.2.3]
b. 1866
11
Charity M Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.3]
b. 1835 d. 23 Mar 1895
Revilo Emmon Tyne Berry
b. 9 Jul 1849 d. 12 Jul 1925
12
Lorenzo "Renzo" Berry
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.3.1]
b. 1 May 1873 d. 17 Oct 1942 [
=>
]
12
Hannah Maria Berry
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.3.2]
b. Abt 1877 d. Jun 1943 [
=>
]
11
Nathan Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.4]
b. 1836 d. 9 Nov 1899
Margaret Unknown
12
Marcia H. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.4.1]
b. 11 Oct 1864 d. 23 Apr 1941 [
=>
]
12
Lizzie Elizabeth Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.4.2]
b. Abt 1867
12
Nora Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.4.3]
b. 11 Jul 1870 d. 1952 [
=>
]
12
Hazel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.4.4]
b. Abt 1894
11
Jesse Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.5]
b. Oct 1836 d. Oct 1909
Elizabeth Barnes
b. Abt 1847 d. 27 Sep 1918
12
Lewis Louis E Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.5.1]
b. 7 Apr 1866 d. 9 Feb 1940 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.5.2]
b. 1867 d. Bef 1941
12
Julia Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.5.3]
b. Nov 1870 d. 21 Sep 1900 [
=>
]
12
Anna Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.5.4]
b. Abt 1876
11
William M Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.6]
b. Oct 1843
Ida M Thurston
b. Jun 1852
12
Corrie E Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.6.1]
b. Abt 1895
11
Charles Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.3.7]
b. 1859
10
Marquis Delafayette Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4]
b. Abt 1806 d. 16 Jun 1890
Elizabeth Betsy Wright
b. 1819 d. 2 May 1887
11
William Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.1]
11
Lewis F Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.2]
b. May 1835 d. 29 Jan 1904
Laura Ann Blowers
b. Abt 1839 d. 28 Aug 1892
12
Flora J. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.2.1]
b. Abt 1867 d. Abt 1940 [
=>
]
12
Jessie M Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.2.2]
b. Abt 1870 d. Abt 1943
12
Daniel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.2.3]
b. 1872
12
Cora Pearl Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.2.4]
b. 11 Jun 1880 d. 11 Jan 1965 [
=>
]
12
Charles Kenyon Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.2.5]
b. 27 Jun 1883 d. Nov 1966 [
=>
]
+
Clara Belle Edson
b. Dec 1851
11
Ursula R Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.3]
b. Sep 1836 d. 1907
+
James Archer
b. Abt 1834
11
George Washington Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.4]
b. Sep 1841 d. 18 Sep 1904
Rachel A. Teets
b. 10 Apr 1847 d. Aft 1920
12
William Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.4.1]
b. Abt 1867
12
John Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.4.2]
b. Abt 1869 d. 1949
12
George M Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.4.3]
b. 3 Dec 1871 d. 1881
12
Charles Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.4.4]
b. Jan 1878 d. 1935
12
Lidy Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.4.5]
b. Jul 1883
Henrietta Hayler
b. 11 Aug 1843 d. 6 Oct 1919
12
Mella Beatrice Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.4.6]
b. Oct 1872 d. 21 Jun 1900 [
=>
]
12
Howard Hugh Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.4.7]
b. 19 Dec 1874 d. 6 Mar 1945 [
=>
]
11
Melissa A. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.5]
b. 1842 d. 23 Jan 1907
11
Susan S. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.6]
b. Aug 1843 d. 16 Feb 1907
William Henry Horr, Sr.
b. 1 Feb 1850 d. 31 Dec 1932
12
William Henry Horr, Jr.
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.6.1]
b. 10 Oct 1877 d. 15 May 1964 [
=>
]
12
Charles Horr
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.6.2]
b. Apr 1880 d. Bef 1900
12
Marquis Franklin Horr
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.6.3]
b. 2 May 1880 d. 1 Jul 1955
12
Eugene Morris Horr
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.6.4]
b. 2 Mar 1884 d. 25 Jun 1939 [
=>
]
12
Gertrude M Birdie Horr
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.6.5]
b. May 1892
11
Isabelle Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.7]
b. 26 Nov 1845 d. 29 Nov 1899
John Arnold Babcock
b. 11 May 1843 d. 28 Jul 1906
12
Minnie Belle Babcock
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.7.1]
b. Mar 1867 d. 17 Jul 1918
12
Myrtle Dell Babcock
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.7.2]
b. Dec 1868 d. Nov 1931 [
=>
]
12
Lyman J. Babcock
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.7.3]
b. Mar 1871 d. Aug 1960 [
=>
]
12
Lois Lulu Mae Babcock
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.7.4]
b. 14 Jun 1874 d. 14 Dec 1968 [
=>
]
12
Charles Ray Babcock
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.7.5]
b. 4 Jul 1878 d. 17 Jul 1928
12
Pearl M. Babcock
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.7.6]
b. 1886 d. 15 Feb 1960
11
Charles Franklin Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.8]
b. 13 Sep 1846 d. 15 Feb 1911
Helen M Orcutt
b. 4 Oct 1845 d. 6 Jun 1921
12
Vance Eldridge Thurston Avery
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.8.1]
b. 6 Oct 1879 d. 26 Feb 1953 [
=>
]
12
Zelma Marion Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.8.2]
b. 26 Oct 1881 d. 16 Dec 1979 [
=>
]
11
Ann Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.9]
b. 1848/1849
11
Addison Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.10]
b. Abt 1851 d. 23 Mar 1907
Sarah Ann Moore
b. 14 Jul 1856 d. 20 Feb 1894
12
Cora Emmeline Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.10.1]
b. 17 May 1879 d. 11 Oct 1951 [
=>
]
11
Adella Ella Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.4.11]
b. 1853 d. 19 Dec 1919
10
Johnson Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.5]
b. 1809 d. 29 Sep 1883
10
Daniel T Thurston, II
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.6]
b. 20 Oct 1809 d. 22 Apr 1900
10
John Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.7]
b. 1812 d. 29 Sep 1896
+
Hannah Babcock
b. 1817 d. 1902
10
Lydia Thurston Fitzgerald
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.8]
b. 1814 d. 1876
Thomas Fitzgerald
b. 1803 d. 1894
11
Daniel Fitzgerald
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.8.1]
b. 1838 d. 22 Apr 1920
+
Rose McGinnis
10
Amelia Malinda Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9]
b. Abt 1815 d. 29 Nov 1861
Silas Hibbard Wheeler
b. Feb 1808 d. 31 Dec 1882
11
Marian Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.1]
b. 1831 d. 1894
Francis Pratt
b. 5 Oct 1829 d. 6 Dec 1864
12
Francis H. Pratt
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.1.1]
b. 1860 d. 1942 [
=>
]
11
Hibbard Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.2]
b. 19 Nov 1833 d. 7 Dec 1894
11
Daniel Hymenus Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.3]
b. 19 Nov 1833 d. 11 May 1901
11
Hymenous Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.4]
b. 19 Nov 1833 d. 11 May 1901
11
Malinda Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.5]
b. 1835
11
Francina Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.6]
b. 1837 d. 19 Oct 1880
11
Celestia Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.7]
b. 3 Oct 1841 d. 12 Dec 1919
11
Jay Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.8]
b. 1843 d. 13 Apr 1856
11
Adelia Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.9]
b. 1845 d. 21 Jul 1924
11
Helen Sedate Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.10]
b. 5 Jan 1847 d. 1925
11
Ermina Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.11]
b. 1848 d. 1927
11
George Tompson Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.12]
b. 1851 d. 1918
11
Gerrit Smith Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.13]
b. 24 Jun 1853 d. 17 Sep 1904
11
Kenneth Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.14]
b. 1854
11
Henrietta Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.15]
b. 1855 d. 12 Oct 1877
11
Violetta Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.16]
b. 1859 d. 23 Feb 1914
11
Flora Valnet Wheeler
[1.2.1.1.1.1.1.2.5.9.17]
b. 9 Sep 1861 d. Oct 1924
9
Hannah Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.2.6]
b. Abt 1778
8
Joel B. Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3]
b. 21 Feb 1739 d. 10 Mar 1833
Miriam Blakely
b. 9 Jun 1738 d. 28 Feb 1819
9
Solomon Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.1]
9
Jason (Joseph) Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.2]
b. Aug 1762 d. 26 Feb 1835
9
William Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.3]
b. 1765 d. 15 Jun 1840
9
Miriam Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.4]
b. 27 Sep 1765 d. 11 Nov 1840
9
Sybil Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.5]
b. 29 Dec 1769 d. 8 Mar 1850
Jedediah Jewett Burdick
b. 1769 d. 5 Dec 1832
10
Matthew Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.1]
b. 7 Feb 1794 d. 11 Feb 1878
10
Daniel J Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2]
b. 27 Sep 1796 d. Mar 1870
Mahala Graves
b. 31 Dec 1806 d. 14 Dec 1899
11
Matilda Jane Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1]
b. Feb 1826 d. 3 Dec 1902
Adam Horr
b. 1817 d. 19 Dec 1898
12
Polly Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.1]
12
Michael Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.2]
12
Mary Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.3]
b. 1847
12
Peter Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.4]
b. May 1848 d. 25 Jun 1910 [
=>
]
12
Walter C. Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.5]
b. 11 Feb 1851 d. 9 Mar 1922 [
=>
]
12
Melissa Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.6]
b. 1852
12
Emma J. Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.7]
b. Apr 1854 d. 23 Jan 1932 [
=>
]
12
Elnora Nora Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.8]
b. Abt 1858 d. 20 Feb 1891 [
=>
]
12
Jennie Mae Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.9]
b. 1860 [
=>
]
12
June Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.10]
b. Abt 1861 [
=>
]
12
James Henry Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.11]
b. 14 Apr 1864 d. 6 Oct 1938 [
=>
]
12
Franklin Albert Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.12]
b. 14 Jan 1868 d. 6 Jun 1946 [
=>
]
12
Julia Annette Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.1.13]
b. Jul 1869 d. 19 Apr 1951 [
=>
]
11
Eliza Jane Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.2]
b. 1827 d. 1888
Matthew Henry Horr
b. 1826 d. 1878
12
William Henry Horr, Sr.
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.2.1]
b. 1 Feb 1850 d. 31 Dec 1932 [
=>
]
12
Charles F. Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.2.2]
b. 28 Dec 1852 d. 16 Apr 1937 [
=>
]
12
Adelia Sarah Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.2.3]
b. Apr 1854 d. 18 Aug 1928 [
=>
]
12
Joseph Joab B. Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.2.4]
b. 1 Apr 1858 d. 10 Feb 1918 [
=>
]
12
Mildred Horr
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.2.5]
b. 1859
11
Susan Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.3]
b. Jun 1831 d. 31 Jan 1894
+
Henry Cummins
b. 1827
11
Mercy M Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.4]
b. 30 Apr 1833 d. 20 Oct 1922
Leroy L Baker
b. Sep 1835 d. 4 Jul 1927
12
Sarah Baker
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.4.1]
b. 1858 d. 18 Apr 1922
12
Albert Baker
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.4.2]
b. 1860 d. 1929
12
Silvanus Edward Baker
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.4.3]
b. 22 Aug 1862 d. 3 May 1958
11
Rebecca Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.5]
b. 30 Sep 1835 d. 19 Feb 1920
+
Orlando George Baker
11
Sarah A Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.6]
b. 1838 d. Bef 1880
11
Mahala Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.7]
b. Abt 1841
+
Dewitt Clinton Koplin
11
Artimetia M Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.8]
b. 18 May 1844 d. 17 Feb 1932
+
Orrin R Griffin
11
Daniel Burdick, Jr.
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.9]
b. 29 Apr 1847 d. 8 Jul 1912
11
Martha Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.10]
b. 1 Jul 1851 d. 18 Jan 1933
Louis W. Bellinger
b. 12 Dec 1845 d. 16 Apr 1924
12
Fred Bellinger
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.10.1]
b. 31 Jul 1867 d. 23 Apr 1956
12
Cora Bellinger
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.10.2]
b. 24 Jun 1869 d. 23 Dec 1951
12
Lillian "Lillie" A Bellinger
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.2.10.3]
b. 23 Dec 1874 d. Apr 1975
10
Anna M Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.3]
b. 2 Jun 1798 d. 29 May 1891
10
Jonathan Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.4]
b. 8 Feb 1800 d. 11 Feb 1882
+
Polly Covey
10
Isaac Jewett Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.5]
b. 25 Nov 1801 d. 21 Mar 1894
10
Sybil Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.6]
b. 14 Sep 1803 d. 8 Mar 1881
10
Olive Minerva Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.7]
b. 2 Aug 1805 d. 25 Jan 1893
Josias Green Crandall
b. 22 Mar 1802 d. 21 Jan 1881
11
Eleanor Minerva Crandall
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.7.1]
b. 18 Oct 1825 d. 23 May 1908
11
Daniel Crandall
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.7.2]
b. 1826
11
Alva Crandall
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.7.3]
b. 1827
11
Edward Thurston Crandall
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.7.4]
b. 26 Feb 1828 d. 13 Aug 1909
11
Dolly Miranda Crandall
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.7.5]
b. 26 Nov 1829 d. 20 Nov 1915
11
Sybil Susan Crandall
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.7.6]
b. 14 Sep 1837 d. 9 Nov 1921
11
Jane Olive Crandall
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.7.7]
b. 24 Mar 1845 d. 4 Jan 1933
10
Eleanor Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.8]
b. 4 Jun 1807 d. 11 Aug 1886
10
Elijah W Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.9]
b. 7 Jun 1808 d. 10 Sep 1898
10
Aaron Jewett Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.10]
b. 26 Dec 1809 d. 8 Dec 1856
10
Leonard Cousin Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.11]
b. 10 Dec 1810 d. 3 Mar 1854
10
Joel Thurston Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.12]
b. 29 Jan 1812 d. 12 May 1881
Caroline Elizabeth Jones
b. 10 Aug 1819 d. 1884
11
Jane Elizabeth Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.12.1]
b. 30 Jul 1838 d. 9 Nov 1911
11
Abelbert Thurston Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.12.2]
b. 14 Sep 1839 d. 21 Aug 1896
11
Harriet J Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.12.3]
b. 1843 d. 1907
11
Ruth M Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.12.4]
b. 29 Sep 1845 d. 7 Sep 1923
11
Caroline Augusta Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.12.5]
b. 27 Aug 1848 d. 27 Sep 1905
11
Daniel Webster Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.12.6]
b. Abt 1850 d. Between 1850 and 1855
11
John Franklin Burdick
[1.2.1.1.1.1.1.3.5.12.7]
b. 8 Nov 1856 d. Aft 1936
9
James Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.6]
b. 14 Aug 1771 d. 18 Aug 1856
9
David Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.7]
b. 1773 d. 1845
9
Rachel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.8]
b. 1773 d. 5 May 1845
Reynolds Kenyon
b. 24 Sep 1762 d. 24 Feb 1845
10
Paris Kenyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.1]
b. 1793 d. 1878
10
Thurston Kenyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.2]
b. 8 May 1795 d. 24 Mar 1879
10
Nathaniel Kenyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.3]
b. 5 Jun 1797 d. 11 Dec 1884
10
Anna Kenyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.4]
b. 11 Sep 1799 d. 1 Aug 1888
10
Phoebe Kinyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.5]
b. 3 Jun 1801 d. 31 Jan 1879
10
Miriam Kenyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.6]
b. 1802 d. 20 Nov 1884
10
Reynolds Kenyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.7]
b. Jul 1806 d. 20 Nov 1881
10
Oliver Perry Kenyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.8]
b. 18 Sep 1808 d. 3 Jan 1893
10
Spink Kenyon
[1.2.1.1.1.1.1.3.8.9]
b. 15 Nov 1811 d. 5 May 1897
9
John Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.9]
b. 22 Jun 1775 d. 10 Mar 1853
9
Daniel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10]
b. 4 Jun 1781 d. 20 Aug 1836
Margaret Burch
b. 1784 d. 18 Mar 1843
10
Mary Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.1]
b. 19 Nov 1804 d. Nov 1832
10
Samuel Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.2]
b. 1805 d. 1805
10
Margaret Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.3]
b. 8 Aug 1806 d. 26 Dec 1884
10
Miriam Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.4]
b. 31 Mar 1809 d. 20 Apr 1890
10
Barbara Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.5]
b. 1811 d. 1816
10
Daniel Madison Thurston, Jr.
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.6]
b. 13 Aug 1813 d. 1885
10
Solomon Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.7]
b. 24 Nov 1815 d. 1900
10
Anna Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.8]
b. 20 Mar 1818 d. 21 Dec 1864
10
Elizabeth Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9]
b. 16 Nov 1819 d. 4 Aug 1858
Joseph Wren
b. 8 Apr 1809 d. 7 Jan 1878
11
Miriam Millie Melissa Wren
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.1]
b. 8 Jan 1840 d. 23 Jul 1920
11
Mary Elizabeth Wren
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.2]
b. 15 Feb 1842 d. 4 Apr 1906
11
Viola Margaret Wren
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.3]
b. 4 Jul 1844 d. 23 Apr 1917
11
Joseph Wren, Jr.
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.4]
b. 1 Jun 1846 d. 15 Aug 1846
11
William Fredrick Wren
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.5]
b. 7 May 1848 d. 15 Apr 1878
11
Phoebe Augusta Wren
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.6]
b. 7 Jul 1850 d. 9 Apr 1934
Wright Barrett Hammond
b. Mar 1845 d. 20 Mar 1902
12
Mabel A Hammond
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.6.1]
b. Abt 1874 d. 30 Jul 1964
12
Alice D Hammond
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.6.2]
b. 13 Jan 1876 d. 10 Apr 1970
12
Jessie Pearl Hammond
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.6.3]
b. Abt 1878 d. 1880
12
Burrie E Hammon
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.6.4]
b. 26 Feb 1880 d. 31 Jan 1972
12
Rose G Hammon
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.6.5]
b. Dec 1885 d. 28 Jul 1972
12
Phoebe Maude Hammond
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.6.6]
b. 10 Jul 1888 d. 17 Aug 1962 [
=>
]
12
Ruth Omega Davis
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.6.7]
b. Abt 1896 d. 24 Jan 1940
11
Harriet Amelia Hattie Wren
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.9.7]
b. 5 Feb 1854 d. 13 Dec 1919
10
Barbara Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.10.10]
b. 14 Oct 1821
9
Samuel Blakely Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.3.11]
b. 15 Jun 1782 d. 1858
8
Ezra Thurston
[1.2.1.1.1.1.1.4]
b. 16 Apr 1752 d. 1800
4
Joseph Thurston
[1.2.1.2]
b. 15 Jul 1640 d. 21 May 1691
Anne Dunbar
5
Daniel Thurston
[1.2.1.2.1]
b. 1670 d. 1704
Sarah Curtis
6
Daniel Thurston
[1.2.1.2.1.1]
b. 1699 d. 6 Sep 1751
7
Cyrus Thurston
[1.2.1.2.1.1.1]
b. 1746 d. May 1807
Mary Guernsey
b. 1750 d. 1816
8
Ebenezer Thurston
[1.2.1.2.1.1.1.1]
d. 1886
Eunice Kelly
9
Azor Thurston
[1.2.1.2.1.1.1.1.1]
b. 22 Feb 1799 d. 20 Jan 1849
2
Henry Thurston
[1.3]
b. Bef 25 Sep 1580 d. 26 Jan 1598
2
John Thurston
[1.4]
b. Bef 5 Apr 1591