Stewarts Genealogy
First Name
Last Name
[Advanced Search]
[Surnames]
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Share
Print
Bookmark
Elizabeth Focell
1562 - 1620 (58 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Elizabeth Focell
[1]
b. 1562 d. 4 Nov 1620
Robert Tilton
b. 1558 d. 7 Aug 1642
2
William Tilton
[1.1]
b. Feb 1586 d. Abt 1652
+
Ursula Pcroft
b. 1586 d. 5 May 1638
+
Unknown
Susanna Morreal
b. Abt 1620 d. 28 Jan 1665
3
Abraham Tilton
[1.1.1]
b. 1638 d. 28 Mar 1728
Deliverance Littlefield
b. 5 Jul 1655 d. May 1732
4
Abraham Tilton, Jr.
[1.1.1.1]
b. 1666 d. 7 Jan 1756
Mary Jacobs
b. 7 Nov 1672 d. 23 Jan 1745
5
Daniel Tilton, Sr.
[1.1.1.1.1]
b. 2 Apr 1697 d. 1759
Sarah Dutch
b. 1708 d. 2 May 1770
6
Elizabeth Tilton
[1.1.1.1.1.1]
b. 4 Sep 1740 d. 17 Oct 1811
Stephen Hale
b. 28 Feb 1728 d. 22 Dec 1778
7
Abigail Greenleaf Hale
[1.1.1.1.1.1.1]
3
Samuel Tilton
[1.1.2]
b. 16 Jun 1640 d. 29 Nov 1731
Hannah Moulton
b. 19 Jun 1645 d. 11 Apr 1720
4
John Tilton
[1.1.2.1]
b. 23 Oct 1670 d. 1759
Sarah Mayhew
b. Abt 1677 d. Bef 1759
5
John Tilton
[1.1.2.1.1]
b. 24 Mar 1706 d. 1783
Sarah Gibbs
b. 8 May 1717
6
Silas Tilton
[1.1.2.1.1.1]
b. Abt 1740 d. 1817
Joanna Churchill
b. 27 Jan 1746/47 d. Yes, date unknown
7
Silas Tilton
[1.1.2.1.1.1.1]
b. Abt 1781 d. 1838
Elizabeth Spencer
b. Abt 1781
8
Alexander Tilton
[1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 1800 d. Mar 1869
8
Jacob Spencer Tilton, o
[1.1.2.1.1.1.1.2]
b. Abt 1801 d. 18 Aug 1854
+
Adelia Reynolds
b. 1808 d. 17 Nov 1894
8
Abigail Tilton
[1.1.2.1.1.1.1.3]
b. Abt 1802 d. Between 1870 and 1872
Hiram Richardson
b. Abt 1799 d. Aft 1880
9
William Spencer Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1]
b. 12 Mar 1821 d. 13 Jul 1900
Maria Hester Miller
b. 1831 d. 26 Feb 1865
10
Roxanna J. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1]
b. Abt 1848 d. 4 Mar 1894
George Washington Trumble
b. 24 Feb 1842 d. 5 Jun 1916
11
Izora Ida Mae Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1]
b. Sep 1863 d. 15 Dec 1929
Reuben Egbert Ware
b. Mar 1861 d. 12 Feb 1932
12
George Sylvester Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1.1]
b. 25 Mar 1882 d. 29 Jul 1961 [
=>
]
12
Grace J. Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1.2]
b. Mar 1886 d. 23 Jan 1964
12
Clara V. Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1.3]
b. Oct 1890 d. 1918 [
=>
]
12
Claude Egbert Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1.4]
b. 21 May 1891 d. 7 Jul 1964 [
=>
]
12
Fred Vernon Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1.5]
b. 12 Feb 1898 d. 26 Oct 1962
12
Mary Roxina Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1.6]
b. 11 Jul 1900 d. 17 Jan 1966 [
=>
]
12
Lloyd A. Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1.7]
b. 5 May 1903 d. 7 Oct 1977
12
Raymond Allen Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.1.8]
b. 17 Jun 1905 d. 17 Jun 1984 [
=>
]
11
Mary Matilda Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.2]
b. 10 Sep 1867 d. 3 Apr 1887
+
Frances H. Everson
11
George Henry Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.3]
b. 11 May 1871 d. 13 Oct 1946
Alza Victoria Cummings
b. Apr 1875 d. 9 Apr 1930
12
Rosa May Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.3.1]
b. 26 Sep 1889 d. 18 Nov 1966 [
=>
]
12
Ira Hugh Trumble, Sr.
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.3.2]
b. 28 Mar 1892 d. 30 Dec 1967 [
=>
]
12
Milo Henry Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.3.3]
b. 1 Apr 1896 d. 25 Oct 1958 [
=>
]
12
Bertha A. Trumbull
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.3.4]
b. 11 May 1899 d. 5 Sep 1980 [
=>
]
12
Pearl Alice Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.3.5]
b. 20 Aug 1903 d. 17 Oct 1970 [
=>
]
12
Fannie Mildred Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.3.6]
b. 31 Jul 1914 d. 9 Aug 1986 [
=>
]
11
William Spencer Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.4]
b. 18 Jul 1872 d. 24 Mar 1943
Harriett Malinda Waite
b. 27 Apr 1876 d. 11 Feb 1960
12
Gladys Viola Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.4.1]
b. 16 Apr 1913 d. 31 Jul 2006 [
=>
]
12
Harry Russell Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.4.2]
b. 27 Sep 1914 d. 8 Jun 2004 [
=>
]
11
Phoebe Jana Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5]
b. Abt 1874 d. 1 Dec 1938
James A Johnson
b. 1868 d. 25 Mar 1931
12
Clara Belle Johnson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5.1]
b. Abt 1895
12
Cora Mae Johnson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5.2]
b. Jun 1896 d. 18 Mar 1949 [
=>
]
12
Raymond Johnson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5.3]
b. Abt 1899
12
Charles Johnson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5.4]
b. Abt 1901
12
Julia Johnson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5.5]
b. 26 Jun 1903 d. Aug 1974
12
Frank Johnson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5.6]
b. 10 Jul 1905 d. Jun 1977
12
Albert Henry Johnson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5.7]
b. Abt 1907 d. 15 Mar 1993
12
Genevieve Gertrude Johnson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.5.8]
b. 13 Oct 1909 d. 6 Nov 1961
11
Julia Ann Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.6]
b. 13 Apr 1875 d. 1953
Amos Hugh Miller
b. 14 Feb 1867 d. 12 Oct 1935
12
Floyd William Miller, Sr
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.6.1]
b. 19 Jul 1893 d. 2 Nov 1982 [
=>
]
12
Jennie Elizabeth Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.6.2]
b. 5 Aug 1895 d. 1 Apr 1945 [
=>
]
12
Julian Spencer Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.6.3]
b. 30 Aug 1897 d. 24 Mar 1969 [
=>
]
12
Mary Roxcina Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.6.4]
b. 2 Feb 1900 d. 4 May 1959 [
=>
]
11
Fannie Mae Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.7]
b. 16 Apr 1878
+
Leroy A. Johnson
b. 28 Jan 1874 d. 2 Dec 1956
11
Robert Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.8]
b. Mar 1880
11
Charles Foy Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9]
b. 21 Apr 1881 d. 5 Jan 1946
Beulah Maude Waite
b. 11 Sep 1890 d. 22 Apr 1947
12
William F. Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.1]
b. 1 Dec 1908 d. 25 Sep 1968 [
=>
]
12
Alice Cloie Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.2]
b. 27 Apr 1910 d. 15 Nov 1994 [
=>
]
12
Charles Myrul Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.3]
b. 6 Jul 1911 d. 14 Feb 1969 [
=>
]
12
Cecil Vernon Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.4]
b. 19 May 1915 d. 24 Feb 1957 [
=>
]
12
Alma Agatha Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.5]
b. 12 Jul 1916 d. 29 Aug 1972 [
=>
]
12
Floyd Anson Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.6]
b. 1 Dec 1918 d. 11 May 1919
12
Julia Mae Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.7]
b. 1 Mar 1920 d. 24 Mar 1986 [
=>
]
12
Dora Arlene Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.8]
b. 27 Jan 1922 d. Jun 1997
12
Fannie Maude Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.9]
b. 30 Sep 1923 d. 29 Aug 2012 [
=>
]
12
Ivan J. Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.10]
b. 28 Nov 1925 d. 8 Dec 2011 [
=>
]
12
June Irene Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.11]
b. 23 Jun 1927 d. 1 Feb 2010 [
=>
]
12
Frances Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.9.12]
b. 1 Feb 1929 d. 9 May 1981
11
Grover Cleveland Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10]
b. Abt 3 Nov 1884 d. May 1964
+
Corrine Courran
b. 30 Apr 1897 d. 4 Oct 1974
Ethel Alva Parkhurst
b. 22 Nov 1888 d. 17 Sep 1929
12
Kenneth Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10.1]
12
Perle A. Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10.2]
b. 31 Mar 1905 d. Sep 1972 [
=>
]
12
Roxanne Mae Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10.3]
b. 16 Oct 1905 d. 14 May 2000 [
=>
]
12
Evelyn A. Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10.4]
b. 4 Sep 1909 d. 22 Jun 1998
12
Amos Hugh Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10.5]
b. 19 Sep 1911 d. 27 Sep 1978 [
=>
]
12
Raymond W. Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10.6]
b. 7 Nov 1911 d. Apr 1982
12
Grover Leroy Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10.7]
b. 1918 d. 1991
12
George A. Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.10.8]
b. 3 Apr 1924 d. 11 Aug 1988 [
=>
]
11
Chloe Alice Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.11]
b. 27 Apr 1885 d. 22 May 1969
Clark Delaucy Alger
b. 21 Feb 1880 d. 5 Nov 1969
12
Rufus Abner Alger
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.11.1]
b. 17 Dec 1903 d. 21 Jan 1978
11
Matilda Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.12]
b. Abt 1887 d. 1887
11
Cora Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.13]
b. Abt 1889 d. Abt 1890
11
Jennie D. Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.14]
b. Abt 1891 d. Abt 1891
11
Frank Trumble
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.1.15]
b. 1893 d. 1893
10
Mary Samantha Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.2]
b. 5 Aug 1851 d. 3 Aug 1920
+
Martin S. Loomis
b. 1847 d. 1925
+
Allen Deparis Trumble
b. 25 Jul 1847 d. 26 Jun 1928
10
Fannie C. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3]
b. Abt 1853 d. 7 Apr 1881
Jacob L. Morrison
b. 2 May 1847 d. 21 May 1906
11
Jacob Spencer Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.1]
b. Aug 1872 d. Mar 1927
+
Mina A. Nestle
b. 1873 d. 15 Feb 1906
+
Myrtle L. Clark
b. 1878 d. 24 Dec 1902
Gertrude A. Jones
b. 12 Jun 1877 d. 16 Dec 1959
12
Cassie Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.1.1]
b. Abt 1907 d. Bef 1999
11
Herbert Benjamin Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.2]
b. 19 Sep 1874 d. 16 Feb 1952
Cora May Clark
b. 16 Apr 1880 d. 1 Feb 1941
12
Howard Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.2.1]
b. 1902 d. 1904
12
Myrtle Mae Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.2.2]
b. 13 Sep 1904 d. 1 May 1990
12
Harold C Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.2.3]
b. 4 May 1908 d. 7 Oct 1977 [
=>
]
12
Fannie Louise Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.2.4]
b. 30 Sep 1914 d. Jan 1990 [
=>
]
+
Millicent Cutcheon
11
Louise A. Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.3]
b. Apr 1877 d. 28 Nov 1960
John F. Westcott
b. Abt 1872
12
Morris H. Westcott
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.3.1]
b. Abt 1902 d. Bef 1980
12
Howard Westcott
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.3.2]
b. 1903 d. Bef 1990 [
=>
]
11
Charles Francis Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.4]
b. 3 Mar 1881
Cora Estella Reynolds
b. Dec 1884 d. Bef 1966
12
Raymond A. Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.4.1]
b. Abt 1906 d. Bef 1999
12
Adelaide F. Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.4.2]
b. Abt 1911 d. Bef 1999
12
Charles Stanley Morrison
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.3.4.3]
10
Solomon Spencer Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4]
b. 6 Mar 1854 d. 28 May 1926
Mary Jane Spencer
b. 7 Aug 1863 d. 29 Nov 1953
11
Hubbard Spencer Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.1]
b. 23 Jan 1880 d. 3 Aug 1960
Lucy Muretta Aldrich
b. 8 Mar 1878 d. 21 Sep 1954
12
Beatrice Elizabeth Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.1.1]
b. 22 Sep 1902 d. 22 Nov 1984 [
=>
]
11
Louis Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.2]
b. 1882 d. 1884
11
Elnora Mabel Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3]
b. 23 Aug 1883 d. 24 Oct 1918
George Gaylord Mason
b. 3 May 1881 d. 10 Sep 1961
12
Emma Retta Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3.1]
b. 13 Oct 1903 d. 19 Oct 1989 [
=>
]
12
Fern Lulu Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3.2]
b. 6 Jun 1905 d. Sep 1991 [
=>
]
12
Mabel Delia Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3.3]
b. 1 Aug 1907 d. 14 Apr 1985 [
=>
]
12
Charles Salmon Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3.4]
b. 16 Jul 1909 d. 10 Aug 1967 [
=>
]
12
Earl H Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3.5]
b. 1910 d. 16 May 1969 [
=>
]
12
Mabel Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3.6]
b. 1911
12
Cora Martha Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3.7]
b. 27 Mar 1913 d. 5 Feb 1999 [
=>
]
12
Freida Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.3.8]
b. 11 Feb 1916 d. 13 Dec 2002 [
=>
]
11
Fannie Mariah Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4]
b. 6 Nov 1885 d. 29 Jan 1976
Avery Ward Towsley
b. 11 Nov 1884 d. 14 May 1943
12
Harriet May Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.1]
b. 26 May 1906 d. 19 Apr 1996
12
Jennie Mae Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.2]
b. 15 Apr 1908 d. 3 Feb 2006 [
=>
]
12
Lucy A. Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.3]
b. 9 Feb 1910 d. 2 Mar 1993 [
=>
]
12
Dorothy Marie Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.4]
b. 10 Jan 1912 d. 10 Nov 1999 [
=>
]
12
Richard Aldon Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.5]
b. 27 Mar 1914 d. 19 Dec 2002 [
=>
]
12
Frances Grace Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.6]
b. 9 Mar 1916 d. 29 Jan 1982 [
=>
]
12
Ruth Cora Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.7]
b. 17 Dec 1917 d. 29 Feb 2000 [
=>
]
12
Darwin Louis Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.8]
b. 6 Jun 1920 d. 24 May 1926
12
Anna C Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.9]
b. 17 Jan 1922 d. 31 Dec 1955
12
Margaret L. Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.10]
b. 21 Apr 1924 d. 16 May 2009
12
Gladys Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.11]
[
=>
]
12
Beverly Jean Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.12]
b. 6 Apr 1928 d. 22 Nov 2005
12
Vernon A. Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.4.13]
b. 27 Sep 1930 d. 7 Feb 2012
11
William D Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.5]
b. 12 Feb 1888 d. 22 Oct 1914
Bessie Mae Towsley
b. 29 Apr 1894 d. 5 Jul 1990
12
Gertrude Frances Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.5.1]
b. 11 Nov 1913
11
Adelia Mary Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6]
b. 3 Feb 1890 d. 14 Apr 1957
Frank L. Mason
b. 25 Apr 1885 d. 12 Aug 1921
12
Louis R. Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6.1]
b. 16 Dec 1909 d. Bef 2000 [
=>
]
12
Harvey Floyd Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6.2]
b. 12 Sep 1911 d. 23 Dec 1968 [
=>
]
12
Willard Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6.3]
b. Abt 1914
12
Lura Belle Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6.4]
b. 6 Jun 1916 d. 1 Jun 1990 [
=>
]
12
Leta Mae Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6.5]
b. 24 Jul 1918 [
=>
]
12
Willard Mason
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6.6]
[
=>
]
Claude Egbert Ware
b. 21 May 1891 d. 7 Jul 1964
12
Vernon Egbert Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6.7]
b. 5 Mar 1926 d. 10 Jan 1927
12
Claude Junior Ware
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.6.8]
b. 17 Aug 1927 d. 15 Feb 1999 [
=>
]
11
Ella M. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.7]
b. 24 Jul 1892 d. 8 Dec 1977
Howard Duane Hubbard
b. 13 Aug 1884 d. 25 May 1950
12
Howard Andrew Hubbard
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.7.1]
b. 11 Nov 1913 d. 19 Dec 1997
12
Lloyd Stanley Hubbard
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.7.2]
b. 4 Nov 1914 d. 14 Feb 1977
12
Mamie A Hubbard
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.7.3]
b. 20 Sep 1916 d. Jul 1974
12
Duane Alexhdrra Hubbard
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.7.4]
b. 25 Aug 1918 d. 29 Apr 2006
12
Augustus Spencer Hubbard
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.7.5]
b. 9 Oct 1922 d. 9 Apr 1999 [
=>
]
12
Ada Hubbard
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.7.6]
b. 20 Mar 1929 d. 23 Nov 2019 [
=>
]
11
Earl Solomon Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.8]
b. 8 Nov 1894 d. 16 Nov 1964
Elnora Spoor
b. 30 Aug 1891 d. 5 Aug 1958
12
Baby Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.8.1]
b. Abt 1917 d. Abt 1917
12
Rita Arietta Marion Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.8.2]
b. 19 Nov 1918 d. 15 Sep 2005 [
=>
]
11
Leon Harvey Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9]
b. 21 Feb 1897 d. 25 Jul 1956
Lucy Caroline Barthel
b. 21 Nov 1907 d. 14 Apr 1980
12
Pauline Lucy Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.1]
b. 26 Oct 1925 d. 31 Mar 2011 [
=>
]
12
Rose Mary Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.2]
[
=>
]
12
Anna Jane Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.3]
b. 5 Apr 1929 d. 7 Aug 2021 [
=>
]
12
Solomon William Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.4]
b. 17 Dec 1930 d. 4 Sep 2003 [
=>
]
12
Catherine Marie Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.5]
b. 2 Mar 1932 d. 3 Apr 2019 [
=>
]
12
Arlene Ruth Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.6]
b. 17 Dec 1933 d. Jan 1934
12
Carl Peter Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.7]
b. 18 Feb 1935 d. 22 Aug 2014 [
=>
]
12
Grace Isabelle Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.8]
[
=>
]
12
Edwin Monroe Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.9.9]
11
George Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.10]
b. Mar 1899 d. Feb 1901
11
Lyda Mae Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11]
b. 8 Jan 1901 d. 30 Mar 1980
+
Eugene Granger
b. Abt 1895 d. Bef 1920
Floyd William Miller, Sr
b. 19 Jul 1893 d. 2 Nov 1982
12
Iva Irene Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11.1]
b. 5 Jun 1920 d. 1920
12
Mary Mae Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11.2]
b. 14 Oct 1922 d. 25 Nov 1978 [
=>
]
12
Amos Hugh Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11.3]
b. 2 Mar 1923 d. 24 Mar 1923
12
Hazel A Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11.4]
b. 1 Aug 1924 d. 21 Aug 2019 [
=>
]
12
Floyd William Miller, Jr
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11.5]
b. 26 Jun 1926 d. 16 Dec 1987 [
=>
]
12
Henry Allen Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11.6]
b. 31 Aug 1931 d. 26 Apr 2004 [
=>
]
12
Julian Spencer Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11.7]
b. 4 May 1932 d. 20 Jan 1933
12
Jennie Lee Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.11.8]
11
Laura Belle Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.12]
b. 5 Sep 1903 d. 7 Aug 1983
Gerold Cortland Cole
b. 2 May 1901 d. 21 Dec 1980
12
Spencer Richardson Cole, Sr.
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.12.1]
b. 5 Feb 1924 d. 1 Oct 1956
12
Garold Cole
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.12.2]
b. 1 Nov 1925 d. 1926
12
Darrow Vernon Cole
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.12.3]
b. 2 Apr 1927 d. 1927
12
Darwin Lewis Cole
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.12.4]
b. 2 Apr 1927 d. 9 Dec 1976
12
George Allen Cole
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.12.5]
b. 30 May 1930 d. 5 Dec 2005 [
=>
]
12
Patricia Ann Cole
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.12.6]
[
=>
]
11
Luella Jane Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.13]
b. 24 Dec 1905 d. 20 May 1986
William Claude Mouck
b. 21 Dec 1904 d. 13 Aug 1960
12
Barbara Louise Mouck
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.13.1]
b. 6 Jun 1925 d. 24 Oct 1984 [
=>
]
12
William Claude Mouck
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.13.2]
b. 22 Apr 1929 d. 17 Dec 1990 [
=>
]
12
Verda Belle Mouck
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.4.13.3]
b. 3 Sep 1932 d. 20 Mar 2016 [
=>
]
10
Baby Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.1.5]
b. Nov 1864 d. Abt 1864
+
Sarah Ann Devall
b. 1828 d. 13 Mar 1895
9
Harrison Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.2]
b. Abt 1824
9
Elizabeth Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.3]
b. Abt 1825
+
Unknown Doherty
9
Rodman Tilton Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.4]
b. 12 Mar 1829
Rosella Unknown
b. Abt 1836
10
Emma R. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.4.1]
b. Abt 1858
10
Charles B. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.4.2]
b. Abt 1863
10
Minnie B. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.4.3]
b. Abt 1867
10
Fredrick Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.4.4]
b. Abt 1871
10
Hiram Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.4.5]
b. 1879
9
Martin Van Buren Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.5]
b. Abt 1831
9
Mary E. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.6]
b. Abt 1834 d. 5 Oct 1878
Abijah Miller
b. 1833 d. 14 Mar 1889
10
Sarah L. Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.6.1]
b. Abt 1857 d. 29 Sep 1888
Frank B. Rickard
b. 5 Mar 1854 d. 26 May 1943
11
Eva Mary Rickard
[1.1.2.1.1.1.1.3.6.1.1]
b. 16 Oct 1885
+
Glenn D. Lewis
b. 1889
10
Emma L. Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.6.2]
b. Abt 1860 d. 6 Apr 1892
+
John E. Jennings
b. 1857 d. 29 Jan 1922
10
Emeline E. Miller
[1.1.2.1.1.1.1.3.6.3]
b. 1860
9
Silas Tilton Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7]
b. Between Jun 1835 and 1840 d. Aft 1903
+
Huldia Anne Tilton
b. 1841 d. May 1909
Caroline Manning
b. Abt 1850 d. 7 Apr 1918
10
Adeline A. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1]
b. 23 Nov 1885 d. 1930
Leroy P. Towsley
b. 31 Jan 1885 d. 18 Jul 1915
11
Charles D. Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.1]
b. 1910
11
Catherine Carrie Arvilla Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.2]
b. 8 Oct 1912 d. 3 Apr 2000
James P Butler
b. 6 Sep 1903 d. 28 Jul 1995
12
Earl P Butler
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.2.1]
b. Abt 1933 d. Feb 2007
12
Lena S Butler
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.2.2]
12
Agnes A Butler
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.2.3]
b. Abt 1938 d. 1996
12
Rosemary Esther Butler
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.2.4]
b. 13 Nov 1946 d. 26 Sep 1999 [
=>
]
12
Darlene Butler
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.2.5]
11
Bertha Mae Towsley
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.3]
b. 19 Nov 1913 d. 13 Oct 1992
Clarence L. Samson
b. 31 Aug 1907 d. 1977
12
Jane A. Samson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.1.3.1]
d. Mar 2004
+
Martin Kilbin
b. 1904
Flora Jane Burnett
b. Abt 1860
10
Silas Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.2]
b. Between Apr and Jun 1897 d. Between Apr and Jun 1897
10
Seth Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.3]
b. Between Apr and Jun 1897 d. Between Apr and Jun 1897
10
Vera Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.4]
b. Sep 1890 d. Bef 1980
10
Lucy Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.5]
b. Nov 1891 d. Bef 1980
10
Josiah Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.6]
b. Apr 1896 d. Bef 1980
10
Hattie Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.7]
b. 22 Feb 1898 d. Mar 1979
10
Florence Olive Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.8]
b. 1 Aug 1900 d. 1976
+
Raymond Armentrout
b. Abt 1900 d. Bef 1980
Joe Barlow
b. Abt 1899 d. Bef 1980
11
Charlotte Louise Barlow
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.8.1]
b. 13 Mar 1918 d. 5 Feb 1994
Morris Lynn Gleason
12
Jerry Lynn Gleason
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.8.1.1]
[
=>
]
12
Karen Lou Gleason
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.8.1.2]
[
=>
]
+
Ray S. Sabin
10
Clifford Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.7.9]
b. 1902 d. Aft 1976
9
Seth C. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.8]
b. 27 Jan 1836
+
Helen Bullis
b. Abt 1835
9
Ezra R. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.9]
b. 1837 d. 1862
9
Charlotte E. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.10]
b. Abt 1839
+
Unknown Vangouser
9
Lenora A. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.11]
b. Abt 1840
+
Theodore Collins
b. Abt 1840
9
Anna G. Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.12]
b. Abt 1843
9
Alice Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.13]
b. Abt 1844
+
Unknown Newbence
9
Hiram Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.14]
b. Abt 1847 d. 1875
9
Abigail Richardson
[1.1.2.1.1.1.1.3.15]
b. Abt 1849
7
Son Tilton
[1.1.2.1.1.1.2]
b. 1782